
Our Family
Genealogy Pages

Unknown Rannde

( = Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
- 1 Unknown Rannde [1]
- 2 George Rannde [1.1]
b. Abt. 1530
Joan Unknown b. Abt 1535
- 3 Joan Rannde [1.1.1]
b. Abt 1553
- 3 Rose Rannde [1.1.2]
b. Abt 1557
- + John Abbot b. Abt 1553
- + John Abbot b. Abt 1553
- 3 Marian Rannde [1.1.3]
b. Abt 1559
- 3 John Rannde [1.1.4]
b. 1560
Joan Unknown b. Abt. 1568
- 4 Jonas Rannde [1.1.4.1]
b. 1590
Maria Sadler b. Abt. 1593
- 5 Thomas Rands [1.1.4.1.1]
b. 1624 d. Jun 1675
Mary Morris b. Abt. 1626 d. 1661
- 6 John Rands [1.1.4.1.1.1]
c. 12 Apr 1658 d. 1713
Tomasin Ford or Foorde b. Abt. 1669 d. 1729
- 7 John Rands [1.1.4.1.1.1.1]
b. 1691 d. 1716
- 7 Robert Rands [1.1.4.1.1.1.2]
b. 1694 d. 21 Dec 1762
- 7 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.3]
b. 1695
- 7 Thomas Rands [1.1.4.1.1.1.4]
b. 1697
- 7 Mary Rands [1.1.4.1.1.1.5]
b. 1700 bur. 21 Nov 1728
- 7 Tomasin Rands [1.1.4.1.1.1.6]
b. 1702
Isaac Reynolds
- 8 Sarah Reynolds [1.1.4.1.1.1.6.1]
b. 1728
- 8 Tomazin Reynolds [1.1.4.1.1.1.6.2]
b. 1734
- 8 Rachael Reynolds [1.1.4.1.1.1.6.3]
b. 1738
- + Richard Moyse c. 26 Sep 1744 bur. 8 Aug 1776
- + Richard Moyse c. 26 Sep 1744 bur. 8 Aug 1776
- 8 Esther Reynolds [1.1.4.1.1.1.6.4]
b. 1739
- 8 Sarah Reynolds [1.1.4.1.1.1.6.1]
- 7 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.7]
b. 1704
- 7 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8]
c. 26 May 1706 d. 1772
Hannah Smith c. 8 Feb 1713 bur. 11 Apr 1755
- 8 Hannah Rands [1.1.4.1.1.1.8.1]
c. 2 Jun 1734
- 8 William Rands [1.1.4.1.1.1.8.2]
c. 29 Dec 1736
- 8 Tomasin Rands [1.1.4.1.1.1.8.3]
c. 18 Jun 1738 d. Jul 1809
John Cutting b. Abt 1736 d. 1803
- 9 Priscilla Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.1]
c. 8 Nov 1761 bur. 15 Aug 1789
William Cook b. Abt 1753 bur. 8 Oct 1827
- 10 William Cook [1.1.4.1.1.1.8.3.1.1]
c. 12 Dec 1787
- 10 William Cook [1.1.4.1.1.1.8.3.1.1]
- 9 Elizabeth Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.2]
b. Abt 1763 bur. 17 Apr 1809
- 9 John Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.3]
c. 30 Sep 1764
- 9 Hannah Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.4]
c. 12 Jul 1767 bur. 5 Feb 1772
- 9 Robert Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.5]
c. 30 Apr 1769
- + Mary Garrod or Garnham bur. 17 Apr 1796
- + Amy Whistle
- + Mary Garrod or Garnham bur. 17 Apr 1796
- 9 William Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.6]
c. 30 Dec 1770 bur. 3 Jan 1771
- 9 Tamerson Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.7]
b. 20 Aug 1772 d. Oct 1809
Nathaniel Garnham b. 1775 d. Oct 1849
- 10 Susan Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.1]
c. 16 Aug 1795
- 10 Amy Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2]
b. 26 May 1797 d. 4th Qtr. 1876
Robert Seager b. Abt 1797 d. Bef 1871
- 11 Robert Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.1]
b. 21 Apr 1821 d. 1905
Eliza Haggar c. 12 Jan 1823 d. Jan 1900
- 12 Elizabeth Emma Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.1.1]
b. 1844 [ =>]
- 12 Isaac Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.1.2]
b. 2 Qtr. 1848
- 12 Thomas Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.1.3]
b. Jan 1853 d. Mar 1853
- 12 Elizabeth Emma Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.1.1]
- 11 Leonard Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2]
b. 30 Mar 1823 d. Apr 1865
Elizabeth Cooper b. 3 Jan 1825 d. May 1895
- 12 Elizabeth Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.1]
b. 16 Nov 1845 d. Feb 1900
- 12 Emma Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.2]
b. 13 Nov 1847 [ =>]
- 12 Amy Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.3]
b. 30 Dec 1849 d. 1st Qtr. 1901 [ =>]
- 12 Hannah Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.4]
b. 1st Qtr. 1852 d. 3rd Qtr. 1895 [ =>]
- 12 Rebecca Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.5]
b. 1854 [ =>]
- 12 Leonard Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.6]
b. 1856 [ =>]
- 12 Ann Florence Mary Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.7]
b. 1858 d. 1892
- 12 John Stephen Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.8]
b. 7 Jun 1861 d. 1885
- 12 Jane Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.9]
b. 22 Jan 1864 d. 16 Nov 1918 [ =>]
- 12 James Seager (later Armstrong) [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.10]
b. Abt 1865
- 12 Elizabeth Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.2.1]
- 11 Elizabeth Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.3]
b. 12 Jun 1825 d. prob 1855
James Armstrong b. 13 Apr 1824 d. Feb 1897
- 12 John Armstrong [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.3.1]
b. 1847
- 12 George Armstrong [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.3.2]
b. 1849 [ =>]
- 12 Edith Armstrong [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.3.3]
b. 1852
- 12 John Armstrong [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.3.1]
- 11 Joseph Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.4]
b. 8 Oct 1827
Eliza Pollard b. 1829 d. 4th. Qtr. 1849
- 12 Leonard Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.4.1]
b. 2nd. Qtr. 1848 d. 2nd. Qtr. 1873
- 12 Leonard Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.4.1]
- + Sarah Pollard b. 1818 d. 1st. Qtr. 1862
- + Hannah Catchpole b. 1835
- 11 David Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5]
b. 17 Jul 1830 d. Jul 1900
Elizabeth b. 1826 d. 10 Nov 1880
- 12 Susannah Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.1]
b. 1851 d. Aft. 1901
- 12 George Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.2]
b. 1854 [ =>]
- 12 Margaret Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.3]
b. Apr 1856 d. May 1856
- 12 Eliza Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.4]
b. 4th. Qtr. 1858 [ =>]
- 12 Robert Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.5]
b. 1861 [ =>]
- 12 Ellen Maria Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.6]
b. 1864
- 12 Alice Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.7]
b. 1st. Qtr. 1866
- 12 Eliza Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.8]
b. 1867
- 12 David Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.9]
b. 1868 [ =>]
- 12 Charlotte Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.10]
b. 3rd. Qtr. 1870 d. Oct 1870
- 12 Alfred Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.11]
b. 1st. Qtr. 1874
- 12 Susannah Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.5.1]
- 11 Robert Seager [1.1.4.1.1.1.8.3.7.2.1]
- 10 Nathaniel Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.3]
c. 28 Jul 1799 d. Sep 1799
- 10 Nathaniel Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4]
b. 2 Aug 1800 d. 7 May 1881
Matilda Daldy b. 1806 d. 30 Dec 1886
- 11 William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1]
b. 21 Nov 1824 d. 1 Qtr. 1901
Martha Rowe b. 1822 d. 1890
- 12 Ezra Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1.1]
b. 1856 d. 1925 [ =>]
- 12 Walter Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1.2]
b. 1857 d. 29 Nov 1874
- 12 Frederick Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1.3]
b. 4th. Qtr. 1859 d. 1936 [ =>]
- 12 Louisa Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1.4]
b. 3rd. Qtr. 1864 [ =>]
- 12 Jane Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1.5]
b. 3 Dec 1865 [ =>]
- 12 Ezra Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1.1]
- 11 James Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2]
b. 12 Sep 1826 d. 2nd Qtr. 1909
Charlotte Simpson b. 1830 d. 3rd. Qtr. 1887
- 12 Matilda Eliza Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.1]
b. 22 Nov 1852 d. 21 Feb 1933 [ =>]
- 12 George William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.2]
b. 4 Sep 1859
- 12 John Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.3]
b. 18 Dec 1862 d. 1927 [ =>]
- 12 Mary Ann Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.4]
b. 18 Dec 1862 [ =>]
- 12 Charlotte Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.5]
b. 23 Oct 1864 d. 1944 [ =>]
- 12 William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.6]
b. 4th. Qtr. 1866
- 12 Edward Charles Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.7]
b. 1st. Qtr. 1869 d. 1922 [ =>]
- 12 Matilda Eliza Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.2.1]
- 11 Elizabeth Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.3]
b. 29 Aug 1828 d. Mar 1866
Robert Whinney b. 1818 d. Nov 1869
- 12 Henry Whinney [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.3.1]
b. 1st. Qtr. 1853
- 12 Alithea Ellen Whinney [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.3.2]
b. 1856
- 12 Louisa Jane Whinney [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.3.3]
b. 25 Oct 1858
- 12 Joseph Whinney [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.3.4]
b. 25 Feb 1861
- 12 Henry Whinney [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.3.1]
- 11 Lucy Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4]
b. 9 Feb 1830 d. Aft. 1918
Benjamin Palmer b. 1830
- 12 William Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.1]
b. Jan 1851
- 12 Maria Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.2]
b. 1854
- 12 Matilda Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.3]
b. 1855
- 12 George Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.4]
b. 1857 d. 2 Sep 1911 [ =>]
- 12 Samuel Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.5]
b. 1859
- 12 Benjamin Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.6]
b. 2nd. Qtr. 1862 [ =>]
- 12 Jane Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.7]
b. 1871
- 12 William Palmer [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.4.1]
- 11 Susan Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5]
b. 9 Jan 1832 d. Sep 1897
John Seadon Roberts b. 1830 d. Feb 1895
- 12 William Seadon Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.1]
b. 1st. Qtr 1852
- 12 George Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.2]
b. 1854
- 12 Henry Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.3]
b. 1856
- 12 Nathaniel Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.4]
b. 1861 [ =>]
- 12 Edith Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.5]
b. 1864
- 12 Ernest Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.6]
b. 1866
- 12 Austin Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.7]
b. 1866
- 12 Susan Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.8]
b. 1868
- 12 Arthur John Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.9]
b. 1st. Qtr 1870
- 12 Walter Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.10]
b. 3rd. Qtr. 1871
- 12 Matilda Anna Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.11]
b. 1st. Qtr. 1873
- 12 Emma Sarah Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.12]
b. 4th. Qtr. 1876
- 12 Sarah Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.13]
b. 2 Jun 1894
- 12 William Seadon Roberts [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.5.1]
- 11 Nathaniel Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6]
b. 27 Jul 1834 d. 5 Feb 1895
Matilda Scarfe or Scarpe b. 1839 d. 26 Mar 1924
- 12 Edith Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.1]
b. 1861 [ =>]
- 12 Isaac Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.2]
b. 1st. Qtr. 1863 d. Oct 1918 [ =>]
- 12 George Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.3]
b. 9 Nov 1864 d. Nov 1949
- 12 Anne Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.4]
b. 2 Oct 1866 d. 1 Jan 1948 [ =>]
- 12 Nathaniel Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.5]
b. 27 Oct 1872 d. 19 Dec 1932
- 12 Matilda Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.6]
b. 24 Jan 1881
- 12 Edith Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.6.1]
- 11 Robert Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7]
b. 6 Apr 1836 d. 1919
Mary Baldry b. 1835 d. 5 May 1910
- 12 Emma Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.1]
b. 1856 [ =>]
- 12 Eliza Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.2]
b. 1858
- 12 Henry Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.3]
b. Aug 1860 d. 18 May 1923 [ =>]
- 12 George Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.4]
b. 1863 d. Prob 1930 [ =>]
- 12 Emily Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.5]
b. 2nd qtr 1864
- 12 Helen Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.6]
b. 4th. Qtr. 1866 d. 1893 [ =>]
- 12 Alice Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.7]
b. 2nd qtr 1868 [ =>]
- 12 Catherine Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.8]
b. 1st qtr 1873
- 12 Emma Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.7.1]
- 11 David Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.8]
b. 24 Feb 1838 d. 30 Jun 1922
- + Frances Cooper b. 17 Feb 1841 d. Jan 1863
Mary Ann Steward b. 1843 d. 30 Apr 1918
- 12 Herbert Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.8.1]
b. 1866 d. Jun 1936
- 12 Ellen Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.8.2]
b. 28 Aug 1870 d. 20 Jun 1940
- 12 Henrietta Mary Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.8.3]
b. 12 Feb 1877 d. 4 Mar 1963 [ =>]
- 12 Herbert Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.8.1]
- + Frances Cooper b. 17 Feb 1841 d. Jan 1863
- 11 Edward Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.9]
b. 1839 d. 23 Apr 1922
Mary Anthoney d. Abt. 1886
- 12 Alice Anthoney Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.9.1]
b. Abt. 1874 d. 8 Apr 1925 [ =>]
- 12 Alice Anthoney Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.9.1]
- + Eliza Matilda Stoneham b. 1st qtr 1857 d. 20 Aug 1905
- 11 John Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10]
b. 26 Dec 1841 d. 5 Feb 1922
Helen Barham b. 14 Feb 1845 d. Nov 1919
- 12 Unknown Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.1]
b. 18 Dec 1867 d. 18 Dec 1867
- 12 Blanch Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.2]
b. 24 May 1869 d. Abt. 1950 [ =>]
- 12 Frank Barham Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.3]
b. 7 Aug 1871 d. Jan 1955 [ =>]
- 12 Amy Rebecca Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.4]
b. 11 Dec 1872 d. Abt 1955 [ =>]
- 12 Albert Edward Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.5]
b. 9 Nov 1874 d. 1940
- 12 John Alfred Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.6]
b. 3rd. Qtr. 1876 d. 1 Feb 1921
- 12 Walter Maurice Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.7]
b. 18 Nov 1877 d. 31 Jul 1878
- 12 Walter Victor Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.8]
b. 14 Apr 1879 d. Jun 1936 [ =>]
- 12 Mabel Beatrice Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.9]
b. 24 Jun 1881 d. 24 Feb 1882
- 12 Helen Constance Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.10]
b. 3 Dec 1882 d. 4 Nov 1966 [ =>]
- 12 Wallace Measor Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.11]
b. 3 Dec 1884 d. 26 Dec 1959 [ =>]
- 12 Merle Florence Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.12]
b. 16 Apr 1889 d. 5 Apr 1950 [ =>]
- 12 Unknown Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.10.1]
- 11 Henry Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11]
b. 1845 d. Oct 1892
Sarah Ann Grist b. 1845
- 12 Edward Herbert Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.1]
b. 1871 d. 1936 [ =>]
- 12 Matilda Emma Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.2]
b. 22 Sep 1873 [ =>]
- 12 Alice Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.3]
b. 14 Feb 1876 d. Jul 1884
- 12 Eva Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.4]
b. 9 Jul 1878
- 12 George Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.5]
b. 15 Mar 1881
- 12 Harry Balmer Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.6]
b. 10 Aug 1883
- 12 Elsie Mabel Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.7]
b. 1887
- 12 Willie Freddy Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.8]
b. 13 Nov 1891
- 12 Edward Herbert Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.11.1]
- 11 George Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.12]
b. 4th Qtr. 1846 d. 4th Qtr 1879
Eliza Lavinia Hadlow b. 1845 d. 1913
- 12 Edgar H Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.12.1]
b. 2nd. Qtr. 1865 [ =>]
- 12 John Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.12.2]
b. 3rd. Qtr. 1869 d. 1939 [ =>]
- 12 Lavinia Annie Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.12.3]
b. 13 Sep 1872 d. 3rd. Qtr. 1952 [ =>]
- 12 Edgar H Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.12.1]
- 11 William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.4.1]
- 10 George Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.5]
c. 5 Sep 1802 d. Jul 1803
- 10 David Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.6]
b. 1 May 1805
- 10 William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.7]
b. 1807 d. 1836
Mary Ann
- 11 William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.7.1]
b. 1829 d. Jan 1898
- 11 William Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.7.1]
- 10 Thomas Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.8]
b. 15 Oct 1809
- 10 Susan Garnham [1.1.4.1.1.1.8.3.7.1]
- 9 Samuel Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.8]
c. 14 Apr 1776
- 9 Joseph Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.9]
c. 4 May 1777 bur. 6 Jun 1782
- 9 Hannah Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.10]
c. 10 May 1783 bur. 30 Sep 1834
- 9 Priscilla Cutting [1.1.4.1.1.1.8.3.1]
- 8 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.8.4]
c. 15 Mar 1740
- 8 Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.5]
c. 14 Apr 1743 bur. 3 Sep 1769
- 8 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.6]
c. 9 Dec 1744 bur. 30 Apr 1811
Elizabeth Buckenham b. Abt 1745 d. Nov 1800
- 9 Hannah Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.1]
b. 1780
- + William Preston b. 1780
- + William Preston b. 1780
- 9 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.2]
b. 10 Mar 1783 bur. 13 Jun 1803
- 9 Keziah Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.3]
b. 7 Feb 1787 bur. 12 Aug 1851
John Hayward b. Abt 1786 bur. 21 Sep 1826
- 10 John William Hayward [1.1.4.1.1.1.8.6.3.1]
b. 20 Jul 1811
- 10 John William Hayward [1.1.4.1.1.1.8.6.3.1]
- 9 Hannah Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.1]
Mary Brett b. 1777 d. Jan 1858
- 9 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.4]
b. 21 Aug 1804
- 9 Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.5]
b. 8 Jun 1805 d. Aug 1805
- 9 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.6]
b. 8 Jun 1805 d. Aug 1805
- 9 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7]
b. 8 Jul 1806 d. 4 Qtr 1885
Rachel Moyse b. Abt. 1805 d. 20 Dec 1878
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.1]
c. 15 Nov 1828
- 10 Isaac Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.2]
b. 9 Oct 1830 d. 2nd Qtr. 1901
- 10 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.3]
c. 6 Oct 1833 d. 3 Qtr. 1902
- 10 Eliza Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.4]
b. 1835 d. 1st Qtr. 1895
- 10 George Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.5]
b. Abt. 1837 d. 3rd Qtr. 1877
- 10 Rose Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.6]
b. Abt. 1842
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.7.1]
- 9 Rhoda Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.8]
b. 10 Apr 1810 d. 28 Oct 1868
- 9 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.8.6.4]
- 8 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.7]
c. 21 Apr 1747 bur. 28 Feb 1748
- 8 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8]
c. 10 May 1750 d. 12 Jan 1837
Mary Martin b. 1749 d. 1806
- 9 Mary Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.1]
b. 24 Sep 1769 d. 17 May 1849
- + Simon Hadleigh b. 1768 bur. 12 May 1848
- + Simon Hadleigh b. 1768 bur. 12 May 1848
- 9 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.2]
b. 1770
- 9 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.3]
b. 1772 d. 5 Jun 1839
Ann Friend d. 28 Jan 1847
- 10 Ann Friend Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1]
c. 4 Dec 1803 d. Aug 1873
James Smith b. Abt. 1794 d. Jul 1871
- 11 William Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.1]
b. 1829
- 11 Julia Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2]
b. Abt. 1834
Frederick Butcher b. 22 Sep 1836
- 12 Louisa Emma Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2.1]
b. 3rd. Qtr. 1861
- 12 Jessie N Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2.2]
b. 2nd. Qtr. 1866
- 12 Laura Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2.3]
b. 2nd. Qtr. 1868
- 12 Frederick James Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2.4]
b. 4th. Qtr. 1870 [ =>]
- 12 Ernest Sylvester Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2.5]
b. 3rd. Qtr. 1874 [ =>]
- 12 Louisa Emma Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.2.1]
- 11 Louisa E Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.3]
b. Abt. 1837
- 11 Israel Silvester Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4]
b. 4th. Qtr. 1838 d. 2nd. Qtr. 1896
Emma Theobald Grayston b. 3rd. Qtr. 1839 d. 1st. Qtr. 1912
- 12 Catherine Ann Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.1]
b. 1st. Qtr. 1864 [ =>]
- 12 Augusta Julia Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.2]
b. 3rd. Qtr. 1865 [ =>]
- 12 Louisa Mary Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.3]
b. 2nd. Qtr. 1867
- 12 Julia Alice Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.4]
b. 2nd. Qtr. 1871 [ =>]
- 12 Arthur Silvester Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.5]
b. 3rd. Qtr. 1872
- 12 William Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.6]
b. 2nd. Qtr. 1875
- 12 Catherine Ann Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.4.1]
- 11 William Smith [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1.1]
- 10 Israel Silvester Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.3.2]
c. 5 Jan 1806
- 10 Emma Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3]
b. 3 Sep 1815 d. 20 May 1891
Samuel Wells b. 15 Oct 1804 d. 1 Sep 1881
- 11 Samuel Sylvester Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1]
b. 14 Jul 1835 d. 17 May 1896
L Harriet Brice b. Abt. 1840 d. 1906
- 12 Julia Emma Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1.1]
b. Abt. 1864
- 12 Francis Brice Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1.2]
b. Abt. 1867
- 12 Ralph Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1.3]
b. Abt. 1869
- 12 Donald Guy Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1.4]
b. Nov 1871 [ =>]
- 12 Frank Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1.5]
b. Abt. 1874 d. 27 Mar 1923
- 12 Julia Emma Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1.1]
- 11 Joshua Rands Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2]
b. 22 Aug 1838 d. 27 Jan 1908
Margaret Hall
- 12 Edwin Charles Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.1]
b. 7 Jan 1863 d. 5 Apr 1896 [ =>]
- 12 Henri Rands Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.2]
b. 24 Jan 1865 d. 5 Aug 1915 [ =>]
- 12 Emma Ozaline Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.3]
b. 25 Jan 1867 d. 25 Jan 1914
- 12 Edwin Charles Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.1]
Francinia Eliza Norris d. 23 Jun 1888
- 12 William Arthur Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.4]
b. 3 Jul 1872 d. 7 Apr 1939 [ =>]
- 12 Mary Francinia Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.5]
b. 23 Oct 1874
- 12 Emily Josephine Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.6]
b. 16 Mar 1877
- 12 Jeannette Eliza Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.7]
b. 1 Jul 1879 d. 8 Nov 1917
- 12 Lillian Adelaide Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.8]
b. 1 Nov 1881
- 12 Chester Joshua Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.9]
b. 24 May 1884 d. Jul 1884
- 12 Louis Norris Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.10]
b. 7 Feb 1886 d. Mar 1886
- 12 Francinia Norris Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.11]
b. 23 Jul 1887 d. Jul 1887
- 12 William Arthur Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.2.4]
- 11 Frederic Israel Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3]
b. 10 Oct 1840 d. 15 Oct 1936
Elenora Mosher b. 5 Jan 1845 d. 5 Feb 1893
- 12 Frederick Mosher Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.1]
b. 15 Nov 1867 d. 20 Mar 1948 [ =>]
- 12 George Samuel Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.2]
b. 26 Nov 1869 d. 8 Sep 1941 [ =>]
- 12 Henri Rands Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.3]
b. 14 Sep 1871
- 12 Lillian Janette Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.4]
b. 8 Nov 1873 d. 16 Nov 1958 [ =>]
- 12 John Daniel Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.5]
b. 9 Feb 1876 d. 26 Feb 1937 [ =>]
- 12 Emma Jane Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.6]
b. 22 Apr 1878 d. 28 Jan 1957 [ =>]
- 12 Mary Elenora Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.7]
b. 14 Aug 1880 d. 19 Apr 1963 [ =>]
- 12 Ralph Emerson Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.8]
b. 9 Feb 1883 d. 19 May 1885
- 12 Clarence Wendell Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.9]
b. 29 Mar 1885 d. 27 Mar 1978 [ =>]
- 12 Lucy Alice Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.10]
b. 28 Jan 1888 d. 25 Mar 1956 [ =>]
- 12 Frederick Mosher Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.1]
Elenora Mosher b. 5 Jan 1845 d. 5 Feb 1893
- 12 Mary Elenora Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.11]
b. 14 Aug 1880 d. 19 Apr 1963 [ =>]
- 12 Mary Elenora Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.3.11]
- 11 Henri Ernest Franklin Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.4]
b. 14 Sep 1843 d. 1 Nov 1927
- + Lydia Daugherty b. Abt. 1847 d. 20 Mar 1870
Anna Maria Crosby b. 2 Jul 1847 d. 3 Apr 1888
- 12 Lillian Anna Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.4.1]
b. 21 Jun 1872 d. 2 Feb 1965
- 12 William Crosby Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.4.2]
b. 4 Aug 1873 [ =>]
- 12 Florence L Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.4.3]
b. 24 Mar 1881
- 12 Lillian Anna Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.4.1]
- + Josephine Augusta Maney
- + Lydia Daugherty b. Abt. 1847 d. 20 Mar 1870
- 11 Arthur Edwin Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.5]
b. 28 Dec 1845 d. 15 Apr 1922
Juliana Althea Kinney b. 5 Jun 1844 d. 7 Aug 1920
- 12 Arthur Kinney Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.5.1]
b. 21 Nov 1868 d. 13 Nov 1934 [ =>]
- 12 Grace Ella Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.5.2]
b. 22 Apr 1870 [ =>]
- 12 Clarence Samuel Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.5.3]
b. 24 Apr 1872 d. 25 Sep 1924 [ =>]
- 12 Ernest Joshua Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.5.4]
b. 9 Sep 1876 d. 1 Jul 1939 [ =>]
- 12 Arthur Kinney Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.5.1]
- 11 Emma Ann Mary Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6]
b. 15 Jan 1848 d. 19 Jan 1913
David Wilson Hunt b. 27 Apr 1839 d. 18 Oct 1930
- 12 Eliphalet C Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.1]
b. 9 Apr 1869 d. 21 Sep 1933 [ =>]
- 12 Samuel Henri Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.2]
b. 8 Feb 1871 d. 26 Aug 1922 [ =>]
- 12 Wilson Percival Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.3]
b. 22 Jan 1873 d. 4 Apr 1948 [ =>]
- 12 Francis Wells Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.4]
b. 16 Feb 1875 d. 26 Apr 1961 [ =>]
- 12 Lillian Ella Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.5]
b. 30 Mar 1877 d. 1 Oct 1956 [ =>]
- 12 Persis Julia Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.6]
b. 28 Dec 1878 d. 22 Feb 1959 [ =>]
- 12 Emma Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.7]
b. 5 Aug 1883 d. 6 Aug 1883
- 12 Jenny Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.8]
b. 5 Aug 1883 d. 5 Aug 1883
- 12 Mary Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.9]
b. 5 Aug 1883 d. 5 Aug 1883
- 12 Eliphalet C Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.6.1]
- 11 Sophia Jeannette Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.7]
b. 16 Apr 1850 d. 30 Jul 1923
Franklin S Wells b. 29 Jul 1840 d. 4 Apr 1908
- 12 Samuel Winchester Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.7.1]
b. 27 Jun 1873 [ =>]
- 12 Francis Allen Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.7.2]
b. 26 Apr 1876 d. 5 Feb 1936 [ =>]
- 12 Arthur Calvin Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.7.3]
b. 26 Sep 1879 d. 2 Oct 1956 [ =>]
- 12 Ruby J Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.7.4]
b. 9 Oct 1888
- 12 Samuel Winchester Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.7.1]
- 11 Frances Lillian Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.8]
b. 18 Jul 1852 d. 18 Apr 1873
- 11 Ella Graves Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.9]
b. 5 Sep 1855 d. 16 Dec 1860
- 11 Samuel Sylvester Wells [1.1.4.1.1.1.8.8.3.3.1]
- 10 Josiah Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.3.4]
b. 25 Nov 1819 d. Jan 1820
- 10 Ann Friend Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.3.1]
- 9 Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.4]
b. 1773 d. 1798
- + Charles Carter b. 1769
- + Charles Carter b. 1769
- 9 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.5]
b. 1774 bur. 29 Aug 1776
- 9 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6]
b. 1776 d. 29 Aug 1823
Sarah Andrews b. 1776 d. 15 Jul 1855
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.1]
b. 2 Apr 1804
- 10 Isaac Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2]
b. 6 Jan 1806 d. 3rd Qtr 1857
Elizabeth Parker b. 11 Apr 1800 d. Mar 1866
- 11 Isaac Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.1]
b. 2 May 1823 bur. 30 Jul 1847
- 11 Emma Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2]
b. 21 Feb 1828
Henry Pollard b. Abt. 1829
- 12 Elizabeth Pollard [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2.1]
b. 3rd. Qtr. 1853
- 12 Emma Pollard [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2.2]
b. 3rd. Qtr. 1856
- 12 Henry Pollard [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2.3]
b. 4th. Qtr. 1858
- 12 Sidney Pollard [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2.4]
b. 1st. Qtr. 1861
- 12 Mary A J Pollard [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2.5]
b. Abt. 1866
- 12 Elizabeth Pollard [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.2.1]
- 11 Eleinor Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.3]
c. 14 Aug 1831
- 11 Sidney Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.4]
b. 29 May 1834
- 11 Sidney Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.5]
b. Abt 1836 d. Pos 4th. Qtr. 1853
- 11 Rachael Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.6]
b. 3rd. Qtr. 1837 d. Pos. 2nd. Qtr. 1858
- 11 Mary Anne Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.7]
b. 3rd. Qtr. 1840 d. 1st. Qtr. 1922
- 12 Edward Asquith Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.7.1]
b. 4th. Qtr. 1859 d. 3rd. Qtr. 1944 [ =>]
- 12 Edward Asquith Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.7.1]
- 11 Hiliary Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.8]
b. Abt. 1840
- 11 Sarah Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.9]
b. 1st. Qtr. 1842
- 11 Isaac Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.2.1]
- 10 Rachel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.3]
b. 27 Feb 1808
- 10 Mary Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.4]
b. 24 Nov 1809
- 10 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5]
b. 9 Dec 1811 d. 1871
Stephen Ranson b. 1808 d. 1886
- 11 James Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1]
b. 1832 d. Aft. 1901
Elizabeth Ramsey b. Abt. 1839 d. Aft. 1901
- 12 Ernest Stephen Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1.1]
b. 4th. Qtr. 1870 d. Aft. 1901
- 12 George Thomas Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1.2]
b. Abt. 1871
- 12 Eliza Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1.3]
- 12 Manofosh Cornelius Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1.4]
b. 10 Jun 1881
- 12 Ernest Stephen Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1.1]
- 11 John Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.2]
b. Abt. 1834
- 11 Sarah Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.3]
b. Abt. 1837
- 11 William Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.4]
b. Abt. 1840
- 11 Eliza Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.5]
b. Abt. 1842
- 11 Thomas Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.6]
b. 1844
Hannah Payne b. Abt. 1841
- 12 Harry Thomas Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.6.1]
b. 1 Oct 1882
- 12 Charlie Stephen Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.6.2]
b. 1st. Qtr. 1884
- 12 Harry Thomas Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.6.1]
- 11 Maria Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7]
b. Abt. 1846
Henry Butcher b. Abt. 1841
- 12 Charles Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.1]
- 12 Sarah Harriet Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.2]
b. Abt. 1868 [ =>]
- 12 Arthur John Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.3]
b. 1st. Qtr. 1870
- 12 William Thomas Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.4]
b. 1873 [ =>]
- 12 George Stephen Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.5]
b. 4th. Qtr. 1879
- 12 Walter Harisson Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.6]
b. 4th. Qtr. 1884
- 12 David James Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.7]
b. 4th. Qtr. 1887 d. 13 Feb 1947 [ =>]
- 12 Daniel Joshua Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.8]
b. 4th. Qtr. 1887
- 12 Daisy Eliza Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.9]
b. 3rd. Qtr. 1889
- 12 Charles Butcher [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.7.1]
- 11 Harriet Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.8]
b. Abt. 1851
- 11 James Ranson [1.1.4.1.1.1.8.8.6.5.1]
- 10 Israel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6]
b. 1 Dec 1814 d. Apr 1876
Ann Avis b. Abt. 1819 bur. 20 Jan 1872
- 11 William Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1]
c. 15 Aug 1841
Caroline Elizabeth Smith b. 1852
- 12 Lily Avis Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1.1]
b. 1875 [ =>]
- 12 Charles H Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1.2]
b. Abt. 1878
- 12 William W Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1.3]
b. 1879
- 12 Mable Florence Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1.4]
b. 1884
- 12 Edith Caroline Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1.5]
b. 1889 d. 2nd. Qtr. 1923 [ =>]
- 12 Lily Avis Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1.1]
- 11 Joseph Thomas Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.2]
c. 24 Mar 1844 d. 1st. Qtr. 1922
- 11 Walter Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.3]
c. 12 Jul 1846 bur. 28 Oct 1890
- 11 Charles Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4]
b. 18 Dec 1848 d. 3 Feb 1920
Susannah Elizabeth Stephenson b. 3rd. Qtr. 1845 d. 7 Nov 1928
- 12 Charles Arthur Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4.1]
b. 4th. Qtr. 1872 [ =>]
- 12 Frank William Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4.2]
b. 1st. Qtr. 1875 [ =>]
- 12 Henry Ernest Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4.3]
b. 4th. Qtr. 1877
- 12 Rose Adelaide Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4.4]
b. 4th. Qtr. 1880
- 12 Herbert Harold Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4.5]
b. 1st. Qtr. 1886 d. Jul 1886
- 12 Charles Arthur Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.4.1]
- 11 Elizabeth Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.5]
b. Abt. 1851 bur. 8 Nov 1854
- 11 Henry Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6]
c. 10 Dec 1855 d. 4th. Qtr. 1934
Mary Anne Snell b. 1st. Qtr. 1860 d. 4th. Qtr. 1931
- 12 Unknown Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.1]
[ =>]
- 12 Sarah Ann Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.2]
b. 14 Dec 1883 d. 7 Jun 1969 [ =>]
- 12 Emma Mabel Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.3]
b. 1st Qtr. 1887
- 12 Eliza Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.4]
b. 3rd. Qtr. 1887 d. Sep 1888
- 12 Emily Caroline Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.5]
b. 4th. Qtr. 1889 [ =>]
- 12 Rose Mary Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.6]
b. 2nd. Qtr. 1892 [ =>]
- 12 Gertrude Maud Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.7]
b. 4th. Qtr. 1894
- 12 Henry Ernest Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.8]
b. 4th. Qtr. 1897 [ =>]
- 12 Unknown Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.6.1]
- 11 Alfred Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7]
b. 27 Apr 1856 d. 23 Dec 1947
Mary Ann Bugg b. 30 Nov 1857 d. 29 Jul 1925
- 12 Wilfred Alfred Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.1]
b. 28 Dec 1877 d. 24 Apr 1939 [ =>]
- 12 Margaret Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.2]
b. 30 Aug 1879 d. 1st. Qtr. 1976
- 12 Happy Anna Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.3]
b. 4 Jan 1881 d. 22 Feb 1967 [ =>]
- 12 George Israel Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.4]
b. 15 Sep 1882 d. 10 Aug 1922 [ =>]
- 12 Martha Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.5]
b. 19 Oct 1884 [ =>]
- 12 Emma Mabel Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.6]
b. 18 Jan 1887 d. 17 Jan 1971
- 12 Arthur Walter John Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.7]
b. 25 Nov 1888 d. 26 Dec 1888
- 12 Ernest Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.8]
b. 9 Nov 1889 d. 27 Dec 1889
- 12 Ethel May Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.9]
b. 11 Jan 1891 d. 19 Sep 1936
- 12 Ruth Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.10]
b. 13 Feb 1892
- 12 Walter Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.11]
b. 8 Oct 1894 d. 18 Apr 1973 [ =>]
- 12 Ernest Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.12]
b. 15 Aug 1896 d. 9 Dec 1896
- 12 Wilfred Alfred Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.7.1]
- 11 Wallace Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.8]
b. Abt. 1861
- 11 Samuel Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.9]
b. 1863 d. Jan 1864
- 11 William Rand [1.1.4.1.1.1.8.8.6.6.1]
- 10 Ruth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.7]
b. Abt 1818 bur. 17 Dec 1820
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.6.1]
- 9 Rachel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.7]
b. 1779
Edward Salter b. 1772 bur. 13 Feb 1851
- 10 Edward Salter [1.1.4.1.1.1.8.8.7.1]
b. 12 Oct 1801 bur. 6 Nov 1801
- 10 Rachel Salter [1.1.4.1.1.1.8.8.7.2]
b. 9 Nov 1803
- 10 Naomi Salter [1.1.4.1.1.1.8.8.7.3]
b. Abt 1813 bur. 1 Mar 1829
- 10 Mary Salter [1.1.4.1.1.1.8.8.7.4]
c. 6 May 1827
- 10 Edward Salter [1.1.4.1.1.1.8.8.7.1]
- 9 Isaac Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8]
b. 1 May 1781 d. 24 Sep 1857
Sarah Short b. 10 Sep 1796 d. 10 Dec 1846
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.1]
b. 24 Oct 1816 d. 21 Oct 1817
- 10 Rachael Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.2]
b. 8 Apr 1818 d. 9 Sep 1819
- 10 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3]
b. 29 Sep 1819 d. 21 Feb 1900
Edward Bullen b. 26 Mar 1815 d. 1858-1861
- 11 Rhoda Ann Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1]
b. 2 May 1845 d. 4th Qtr 1882
Thomas Edward Randall b. 1 May 1843 d. 7 Feb 1915
- 12 Edward Thomas Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.1]
b. 3 Apr 1865 d. 3 Apr 1934 [ =>]
- 12 Rhoda Ann Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.2]
c. 1 Nov 1868 [ =>]
- 12 Harriet Sarah Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.3]
b. 15 Jul 1870 d. May 1922 [ =>]
- 12 Thomas Charles W Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.4]
b. 12 Nov 1872 d. 1st Qtr 1874
- 12 Henry George Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.5]
c. 7 Jun 1874 d. 1st Qtr 1875
- 12 John Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.6]
b. 4th Qtr 1875 [ =>]
- 12 James Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.7]
b. 4th Qtr 1877 bur. 7 Mar 1918 [ =>]
- 12 Rebecca Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.8]
b. 4th Qtr 1879 [ =>]
- 12 Arthur William Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.9]
b. 4th Qtr 1881 d. 3rd Qtr 1882
- 12 Edward Thomas Randall [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1.1]
- 11 Edward Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.2]
b. 4th Qtr 1846
- + Catherine Jones b. Abt 1858 d. 4th Qtr 1903
- + Catherine Jones b. Abt 1858 d. 4th Qtr 1903
- 11 George Edward Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3]
b. 19 Apr 1849 d. 20 Feb 1911
Susan Ann Remnant b. 22 Apr 1860 d. 4th Qtr 1939
- 12 Sarah Ann Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.1]
b. 24 Oct 1879 d. 3 Jul 1963 [ =>]
- 12 Georgina Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.2]
b. 3 Aug 1882 d. 19 Jan 1953
- 12 Edward Thomas Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.3]
b. 24 Feb 1885 [ =>]
- 12 Alice Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.4]
b. 8 Apr 1887 d. 3rd Qtr 1887
- 12 Susan Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.5]
b. 8 Apr 1887 d. 1st Qtr 1959 [ =>]
- 12 Frances Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.6]
b. 5 Sep 1888
- 12 George Edward Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.7]
b. 21 Dec 1890 d. 2nd Qtr 1968 [ =>]
- 12 Arthur Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.8]
b. 15 Jul 1892 d. Apr 1980 [ =>]
- 12 Rhoda Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.9]
b. 1st Qtr 1894 d. 1st Qtr 1894
- 12 Frederick Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.10]
b. 27 May 1895 d. 15 Dec 1940
- 12 Elsie Mabel Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.11]
b. 8 Dec 1896 d. 20 May 1922 [ =>]
- 12 Annie Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.12]
b. 7 Sep 1898 d. Apr 1989 [ =>]
- 12 Ellen Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.13]
b. 11 Jun 1903 d. 3rd Qtr 1979 [ =>]
- 12 Sarah Ann Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.3.1]
- 11 John Isaac Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.4]
b. 9 Aug 1851 d. 27 Apr 1854
- 11 Annie Sarah Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5]
b. 24 Dec 1858 d. 22 Dec 1934
Charles Akehurst b. 9 Mar 1854 d. 21 Aug 1933
- 12 Frederick Mongomery Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.1]
b. 31 Oct 1873
- 12 Elizabeth Sarah Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.2]
b. 8 Sep 1877 d. 14 Dec 1957 [ =>]
- 12 Annie Loiuse Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.3]
b. 22 Apr 1880 [ =>]
- 12 Charles Edward Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.4]
b. 15 Jul 1882 d. 15 Feb 1963 [ =>]
- 12 Rhoda Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.5]
b. 2 Jan 1885 d. 3 Apr 1941 [ =>]
- 12 Henry George Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.6]
b. 7 Jan 1887 d. 23 Feb 1887
- 12 Arthur George Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.7]
b. 4 Sep 1888 d. 7 Feb 1914
- 12 John Isaac Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.8]
b. 9 Jul 1891 d. 16 Jan 1892
- 12 Edward Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.9]
b. 7 Dec 1892 d. 9 Apr 1917
- 12 George Walter Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.10]
b. 5 Aug 1895 d. 31 Jul 1692 [ =>]
- 12 Emma Philadelphia Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.11]
b. 27 Jun 1898 d. 19 Feb 1937 [ =>]
- 12 Caroline Pretoria Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.12]
b. 21 Jul 1900 d. 3 Oct 1987 [ =>]
- 12 Alfred James Akehurst [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.13]
b. 28 Aug 1904 d. 27 Aug 1905
- 12 Frederick Mongomery Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.5.1]
- 11 Rhoda Ann Bullen [1.1.4.1.1.1.8.8.8.3.1]
- 10 Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.4]
b. Sep 1821 d. Sep 1821
- 10 Sophia Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.5]
b. 10 Apr 1823 d. 19 Mar 1897
Thomas Buther b. 1819
- 11 Thomas Buther [1.1.4.1.1.1.8.8.8.5.1]
b. 5 Jul 1847 d. 6 Oct 1848
- 11 Thomas Buther [1.1.4.1.1.1.8.8.8.5.1]
- 10 Israel Edward Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6]
b. 7 Jun 1825 d. 12 Sep 1904
Eliza Myers b. Abt 1825 d. 21 Apr 1907
- 11 Edwin Henry Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.1]
b. 10 Apr 1848 d. 6 Jan 1850
- 11 Louisa Caroline Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2]
b. 14 Jun 1850 d. 7 Jul 1943
Thomas Webb b. 9 Apr 1844 d. 17 Apr 1919
- 12 Catherine May Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.1]
b. 4 Feb 1872 d. 3 Jun 1958 [ =>]
- 12 Eliza Caroline Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.2]
b. 12 Jun 1874 d. 1953
- 12 Margaret Ann Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.3]
b. 30 Jul 1875 d. 15 Oct 1967 [ =>]
- 12 Thomas Joseph Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.4]
b. 7 Sep 1877 d. 20 Nov 1958 [ =>]
- 12 Sarah Henrietta Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.5]
b. 19 Aug 1879 d. 10 Jun 1909 [ =>]
- 12 John Alexander Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.6]
b. 28 Mar 1883 d. 1 Aug 1966 [ =>]
- 12 Arthur Andrew Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.7]
b. 23 May 1885 d. 26 Nov 1885
- 12 Francis James Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.8]
b. 23 May 1888 d. 17 May 1971 [ =>]
- 12 Edward Lewis Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.9]
b. 14 Oct 1892 d. 4 Feb 1984 [ =>]
- 12 Catherine May Webb [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.2.1]
- 11 William Thomas Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.3]
b. 27 Aug 1852 d. 27 Aug 1852
- 11 John Alexander Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4]
b. 2 Dec 1857 d. 22 Nov 1942
Janet Mary Paterson b. 12 Aug 1859 d. 26 Mar 1936
- 12 John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.1]
b. 22 May 1883 d. 18 Apr 1968 [ =>]
- 12 Eliza Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.2]
b. 25 May 1884 d. 19 Jan 1968 [ =>]
- 12 Jessie Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.3]
b. 2 Jun 1886 d. 18 Jun 1925 [ =>]
- 12 Alexander Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.4]
b. 26 May 1888 d. 24 May 1982 [ =>]
- 12 Catherine Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.5]
b. 26 Jun 1890 d. 14 Jul 1990
- 12 Annie Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.6]
b. 20 Jul 1892 d. 12 May 1937 [ =>]
- 12 Albert Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.7]
b. 16 Dec 1894 d. 3 May 1917
- 12 Ethel May Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.8]
b. 4 Jul 1899 d. 1972 [ =>]
- 12 John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.4.1]
- 11 Sarah Henrietta Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5]
b. 19 Dec 1859 d. 15 May 1897
William Arthur Grey b. 23 Sep 1861 d. 28 Oct 1941
- 12 Arthur Henry Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.1]
b. 10 Dec 1884 d. 18 May 1957 [ =>]
- 12 Dulcie Henrietta Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.2]
b. 27 Mar 1886 d. 18 Oct 1959 [ =>]
- 12 Lydia Evelyn Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.3]
b. 18 Aug 1887 d. 10 Nov 1965 [ =>]
- 12 Victor Albert Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.4]
b. 1888 d. 26 Jun 1969
- 12 William Bertram Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.5]
b. 1890 d. 1965
- 12 Horace Leslie Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.6]
b. 1891 d. 1 Aug 1915
- 12 Devonshire Dickson Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.7]
b. 31 Aug 1892 d. 3 Mar 1971 [ =>]
- 12 Ronald Lewis Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.8]
b. 1893 d. 1897
- 12 Arthur Henry Grey [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.5.1]
- 11 Lydia Eliza Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6]
b. 15 Sep 1861 d. 10 Nov 1893
John Rutherford Lyon b. 13 Dec 1834 d. 4 May 1893
- 12 Henry Baker Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.1]
b. 9 Feb 1879 d. 5 Jun 1971
- 12 John Rutherford Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.2]
[ =>]
- 12 Edith Eliza Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.3]
b. 9 Aug 1882 d. 24 Jan 1979 [ =>]
- 12 Albert Alan Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.4]
b. 2 Nov 1884 d. 2 Oct 1975
- 12 Jessie Ellen Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.5]
b. 20 Jun 1887 d. 10 Apr 1968 [ =>]
- 12 William Arthur Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.6]
b. 20 Oct 1889 d. 16 Mar 1976 [ =>]
- 12 Israel Edward Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.7]
- 12 Henry Baker Lyon [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.6.1]
- 11 Albert Edward Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7]
b. 2 Aug 1867 d. 1 Jun 1952
Agnus Robina Jennings b. 28 Feb 1878 d. 26 Aug 1964
- 12 Agnes Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.1]
b. Nov 1897 d. Nov 1897
- 12 Albert Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.2]
b. Jul 1898 d. Jul 1898
- 12 Phillip Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.3]
b. 30 Jul 1899 d. 22 Jun 1983 [ =>]
- 12 Richard Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.4]
b. 4 Aug 1901 d. 5 Aug 1901
- 12 Lydia Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.5]
b. 1 Oct 1902 d. 9 Mar 1904
- 12 Leslie Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.6]
b. 22 Sep 1904 d. 23 Sep 1904
- 12 Albert Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.7]
b. 2 Oct 1905 d. 2 Oct 1905
- 12 Agnes Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.7.1]
- 11 Edwin Henry Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.6.1]
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7]
b. 27 Aug 1827 d. 11 Oct 1875
Sarah Anderson b. 12 Apr 1829 d. 20 Sep 1880
- 11 Henry James Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.1]
b. 30 May 1848 d. 17 May 1862
- 11 Sarah Rhodia Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2]
b. 14 Jan 1851 d. 6 Nov 1908
James Neal b. 6 Feb 1850
- 12 Annie Sophia Neal [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.1]
b. 1 May 1869 d. 19 Sep 1961 [ =>]
- 12 Annie Sophia Neal [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.1]
- + Andrew Isaac Whittaker b. 24 Dec 1812 d. 28 May 1874
John Hyde Leigh b. 9 Mar 1833 d. 14 Jan 1911
- 12 John William Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.2]
b. 2 Dec 1871 d. 2 Dec 1871
- 12 Joseph Henry Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.3]
b. 2 Dec 1871 d. 2 Dec 1871
- 12 Sarah Jane Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.4]
b. 18 Mar 1873 d. 24 Feb 1936 [ =>]
- 12 Lulie Ann Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.5]
b. 14 Aug 1875 d. 17 Mar 1894
- 12 Rose Ellen Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.6]
b. 19 Nov 1878 d. 25 Jun 1956 [ =>]
- 12 George Henry Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.7]
b. 1 Mar 1881 d. 24 Aug 1954
- 12 Nora Louise Adelia Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.8]
b. 15 Mar 1884 d. Oct 1941
- 12 William Clarence Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.9]
b. 20 May 1887 d. 14 May 1964
- 12 Abraham Vernand Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.10]
b. 2 Apr 1892 d. 29 Oct 1894
- 12 John Elmer Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.11]
b. 13 Apr 1896 d. 3 Dec 1918
- 12 John William Leigh [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.2.2]
- 11 Joseph William Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3]
b. 29 Jan 1854 d. 23 Feb 1911
Louisa Eliza Sadler b. 27 Aug 1860 d. 19 Sep 1907
- 12 William Edwin Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3.1]
b. 2 Jul 1880 d. 29 May 1959 [ =>]
- 12 Raymond Samuel Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3.2]
b. 13 Oct 1883 d. 24 Aug 1885
- 12 Arthur Leroy Rands, Snr. [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3.3]
b. 11 Apr 1887 d. 7 Jun 1932 [ =>]
- 12 Inez Louise Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3.4]
b. 9 Oct 1892 d. 21 Aug 1977
- 12 Irvin John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3.5]
b. 15 Aug 1896 d. 16 Dec 1987
- 12 William Edwin Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.3.1]
- + Jane Siddall b. 29 Jul 1858 d. Feb 1916
- 11 Lydia Jane Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.4]
b. 21 Dec 1856 d. 16 Nov 1920
- 11 Hyrum Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.5]
b. 1 Jul 1859 d. 9 Oct 1942
- 11 Jessie Lavinia Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.6]
b. 13 Mar 1862 d. 28 Feb 1945
- 11 Helena Ruth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.7]
b. 31 Jul 1864 d. 28 Dec 1879
- 11 Martha Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.8]
b. 28 Mar 1870 d. 18 Sep 1870
- 11 Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.9]
b. 28 Mar 1870 d. 22 Oct 1916
- 11 Henry James Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.7.1]
- 10 John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.8]
b. 15 Aug 1829 d. 8 Jun 1905
Henrietta Marcham b. 14 Apr 1833 d. 30 Dec 1902
- 11 John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.8.1]
b. 9 Nov 1857 d. 5 Sep 1933
- 11 John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.8.1]
- 10 Rhodia Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.9]
b. 2 Mar 1832 d. 10 Sep 1833
- 10 Lydia Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.10]
b. 25 Mar 1898 d. 1st Qtr. 1912
Philip Hunt b. 7 Jul 1836 d. 1st Qtr. 1909
- 11 Samuel Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.8.10.1]
c. 4 Mar 1860 bur. 23 Apr 1860
- 11 Annie Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.8.10.2]
c. 19 May 1861
- 11 Lucy Jane Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.8.10.3]
b. 5 Jun 1863 d. 4th. Qtr. 1920
- 11 Philip Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.8.10.4]
b. 4th Qtr 1871 d. 14 Sep 1905
- 11 Samuel Hunt [1.1.4.1.1.1.8.8.8.10.1]
- 10 Joseph Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.8.1]
- 9 Ruth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.9]
b. 30 Mar 1785
- 9 John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.10]
c. 17 Feb 1788
- 9 Sarah Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.11]
b. Feb 1791
- 9 Simon Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12]
b. 22 May 1795
Elizabeth /Page Sage b. Abt. 1799
- 10 Simon Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1]
b. 3 Feb 1816 d. 10 May 1853
Ann Graham b. Abt. Sep 1821 d. 1st qtr 1904
- 11 Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.1]
b. Abt. 1846
- 11 Simon Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.2]
b. 17 Jan 1851 d. 3rd. Qtr. 1906
Elizabeth Button b. Abt 1855/7 d. Nov 1913
- 12 Louisa Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.2.1]
b. 30 Jun 1881 d. 8 Jun 1947 [ =>]
- 12 Rosina Annie Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.2.2]
b. 10 Oct 1886 d. Mar 1985 [ =>]
- 12 Frank John Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.2.3]
b. 2nd. Qtr. 1890 d. 3rd. Qtr. 1965 [ =>]
- 12 Louisa Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.2.1]
- 11 Elizabeth Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.3]
b. Abt. 1864
- 11 Ann Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1.1]
- 10 Simon Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.12.1]
- 9 Mary Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.1]
Sarah Church c. 11 Jun 1775 bur. 29 Nov 1857
- 9 Maria Church [1.1.4.1.1.1.8.8.13]
b. 18 Jul 1810
- 9 Hannah Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.14]
b. 18 Jul 1816 d. 3rd Qtr. 1876
- 9 David Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.15]
b. Abt. 1818
- 9 James Rands [1.1.4.1.1.1.8.8.16]
b. 17 Feb 1820 bur. 2 Feb 1822
- 9 Maria Church [1.1.4.1.1.1.8.8.13]
- 8 William Rands [1.1.4.1.1.1.8.9]
c. 8 Sep 1754
- 8 Hannah Rands [1.1.4.1.1.1.8.1]
Martha Turpentine b. Abt 1714 bur. 18 Nov 1732
- 8 Martha Rands [1.1.4.1.1.1.8.10]
c. 25 Jun 1729 d. 18 Nov 1732
- 8 Bridget Rands [1.1.4.1.1.1.8.11]
c. 16 Dec 1730 bur. 23 Feb 1740/1
- 8 Anna Rands [1.1.4.1.1.1.8.12]
c. 5 Nov 1732 bur. 14 Nov 1732
- 8 Martha Rands [1.1.4.1.1.1.8.10]
- + Mary Peake Mayhew b. 1714
- 7 John Rands [1.1.4.1.1.1.1]
- 6 John Rands [1.1.4.1.1.1]
- 5 Thomas Rands [1.1.4.1.1]
- 4 John Rannde [1.1.4.2]
b. Abt 1603
- + Martha Finche b. Abt 1607
- + Martha Finche b. Abt 1607
- 4 Edmund Rannde [1.1.4.3]
b. Abt 1605
- 4 Robert Rannde [1.1.4.4]
b. Abt 1606
- 4 Jonas Rannde [1.1.4.1]
- 3 Katherine Rannde [1.1.5]
b. 1561
- 3 Elizabeth Rannde [1.1.6]
b. Abt 1568
- 3 George Rannde [1.1.7]
b. Abt 1570
- 3 Joan Rannde [1.1.1]
- 2 George Rannde [1.1]